500 miles du Michigan

500 miles du Michigan
Tracé de la course
Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈
Données de course
Nombre de tours 250
Longueur du circuit 3,219 km
Distance de course 804,67 km
Résultats

Les 500 miles du Michigan (Michigan 500) ou Firestone Indy 400 de 2002 à 2007, sont une course du championnat américain de course automobile se déroulant entre 1968 et 2007 sur le circuit en oval Michigan International Speedway, dans l'État du Michigan, en États-Unis.

Noms officiels

Les différents noms officiels de l'épreuve au fil des éditions :

  • Norton Michigan 500 (1981-1983)
  • Michigan 500 (1984-1986)
  • Marlboro 500 (1987-1996)
  • U.S. 500 presented by Toyota (1997-1999)
  • Michigan 500 presented by Toyota (2000)
  • Harrah's 500 presented by Toyota (2001)
  • Michigan Indy 400 (2002, 2004-2005)
  • Firestone Indy 400 (2003, 2006-2007)

Résultats

Saison Date Nom Vainqueur Écurie Constructeur Moteur Distance Temps Vitesse moy.
(mph)
Laps Miles (km)
USAC Championship Car
1968 13 octobre Michigan Inaugural 250 Ronnie Bucknum All American Racers Eagle Offenhauser 125 250 (402.336) 1:32:42 161.812
1969 Not held
1970 4 juillet Michigan Twin 200s Gary Bettenhausen Bettenhausen Racing Gerhardt Offenhauser 100 200 (321.868) 1:25:20 138.67
1971 18 juillet Michigan 200 Mark Donohue Penske Racing McLaren Offenhauser 100 200 (321.868) 1:22:09 144.898
1972 16 juillet Michigan 200 Joe Leonard Vel's Parnelli Jones Racing Parnelli Offenhauser 100 200 (321.868) 140.685
1973 15 juillet Michigan 200 Roger McCluskey Lindsey Hopkins Racing McLaren Offenhauser 100 200 (321.868) 1:14:28 161.146
16 septembre Michigan Twin 125s Bill Vukovich Jr. Jerry O'Connell Racing Eagle Offenhauser 63 126 (202.777) 0:56:24 134.026
Johnny Rutherford Bruce McLaren Motor Racing McLaren Offenhauser 63 126 (202.777) 0:48:05 157.243
1974 21 juillet Michigan 200 Bobby Unser All American Racers Eagle Offenhauser 100 200 (321.868) 1:14:41 160.695
15 septembre Norton 250 Al Unser Vel's Parnelli Jones Racing Eagle Offenhauser 125 250 (402.336) 1:45:32 142.135
1975 20 juillet Norton 200 A. J. Foyt A.J. Foyt Enterprises Coyote Foyt 100 200 (321.868) 1:15:31 158.907
13 septembre Michigan 150 Tom Sneva Penske Racing McLaren Offenhauser 75 150 (241.401) 0:51:05 176.16
1976 18 juillet Norton Twin 200s Gordon Johncock Patrick Racing Wildcat DGS 100 200 (321.868) 1:12:43 1:12:43
18 septembre Michigan 150 A. J. Foyt A.J. Foyt Enterprises Coyote Foyt 75 150 (241.401) 0:54:51 164.058
1977 17 juillet Norton 200 Danny Ongais Interscope Racing Parnelli Cosworth 100 200 (321.868) 1:20:27 149.152
17 septembre Michigan Grand Prix Gordon Johncock Patrick Racing Wildcat DGS 75 150 (241.401) 0:51:21 175.25
1978 16 juillet Norton Twin 200 Johnny Rutherford Bruce McLaren Motor Racing McLaren Cosworth 100 200 (321.868) 1:15:02 159.941
16 septembre Gould Grand Prix Danny Ongais Interscope Racing Parnelli Cosworth 75 150 (241.401) 1:01:32 146.246
CART Indy Car World Serie
1979 15 juillet Norton Twin 125s Gordon Johncock Patrick Racing Penske Cosworth 63 126 (202.777) 0:44:13 170.796
Bobby Unser Penske Racing Penske Cosworth 63 126 (202.777) 0:48:40 155.342
15 septembre Gould Grand Prix Bobby Unser Penske Racing Penske Cosworth 75 150 (241.401) 0:51:22 175.211
1980 20 juillet Norton 200 Johnny Rutherford Chaparral Cars Chaparral Cosworth 100 200 (321.868) 1:20:48 148.515
20 octobre Gould Grand Prix Mario Andretti Penske Racing Penske Cosworth 75 150 (241.401) 0:53:44 167.494
1981 25 juillet Norton Michigan 500 Pancho Carter Alex Morales Autosport Penske Cosworth 250 500 (804.672) 3:45:45 132.89
20 septembre Detroit News Grand Prix Rick Mears Penske Racing Penske Cosworth 74* 148 (238.182) 1:10:30 125.957
1982 18 juillet Norton Michigan 500 Gordon Johncock Patrick Racing Wildcat Cosworth 250 500 (804.672) 3:14:54 153.925
26 septembre Detroit News Grand Prix Bobby Rahal Truesports March Cosworth 75 150 (241.401) 1:04:03 140.515
1983 17 juillet Norton Michigan 500 John Paul Jr. VDS Penske Cosworth 250 500 (804.672) 3:42:27 134.862
18 septembre Detroit News Grand Prix Rick Mears Penske Racing Penske Cosworth 100 200 (321.868) 1:05:49 182.235
1984 22 juillet Michigan 500 Mario Andretti Newman/Haas Racing Lola Cosworth 250 500 (804.672) 3:44:45 133.482
24 septembre Detroit News Grand Prix Mario Andretti Newman/Haas Racing Lola Cosworth 100 200 (321.868) 1:11:12 168.523
1985 28 juillet Michigan 500 Emerson Fittipaldi Patrick Racing March Cosworth 250 500 (804.672) 3:53:58 128.22
22 septembre Detroit News 200 Bobby Rahal Truesports March Cosworth 100 200 (321.868) 1:13:19 163.647
1986 2 août Michigan 500 Johnny Rutherford Alex Morales Autosport March Cosworth 250 500 (804.672) 3:38:45 137.139
28 septembre Pepsi Cola 250 Bobby Rahal Truesports March Cosworth 125 250 (402.336) 1:22:33 181.701
1987 2 août Marlboro 500 Michael Andretti Kraco Racing March Cosworth 250 500 (804.672) 2:54:56 171.493
1988 7 août Marlboro 500 Danny Sullivan Penske Racing Penske Chevrolet 250 500 (804.672) 2:46:03 180.654
1989 6 août Marlboro 500 Michael Andretti Newman/Haas Racing Lola Chevrolet 250 500 (804.672) 3:07:15 160.21
1990 5 août Marlboro 500 Al Unser Jr. Galles/Kraco Racing Lola Chevrolet 250 500 (804.672) 2:38:07 189.727
1991 4 août Marlboro 500 Rick Mears Penske Racing Penske Chevrolet 250 500 (804.672) 2:59:23 167.23
1992 2 août Marlboro 500 Drapeau du Canada Scott Goodyear Walker Racing Lola Chevrolet 250 500 (804.672) 2:48:53 177.265
1993 1 août Marlboro 500 Drapeau du Royaume-Uni Nigel Mansell Newman/Haas Racing Lola Ford-Cosworth 250 500 (804.672) 2:39:24 188.203
1994 31 juillet Marlboro 500 Drapeau du Canada Scott Goodyear King Racing Lola Ford-Cosworth 250 500 (804.672) 3:07:44 159.8
1995 30 juillet Marlboro 500 Scott Pruett Patrick Racing Lola Ford-Cosworth 250 500 (804.672) 3:07:52 159.676
1996 May 26 Inaugural U.S. 500 Jimmy Vasser Chip Ganassi Racing Reynard Honda 250 500 (804.672) 3:11:48 156.403
28 juillet Marlboro 500 André Ribeiro Tasman Racing Lola Honda 250 500 (804.672) 3:16:33 152.627
1997 27 juillet U. S. 500 Presented by Toyota Drapeau de l'Italie Alex Zanardi Chip Ganassi Racing Reynard Honda 250 500 (804.672) 2:59:35 167.044
1998 26 juillet U. S. 500 Presented by Toyota Drapeau du Canada Greg Moore Forsythe Racing Reynard Mercedes 250 500 (804.672) 3:00:48 165.913
1999 25 juillet U. S. 500 Presented by Toyota Tony Kanaan Forsythe Racing Reynard Honda 250 500 (804.672) 2:41:12 186.097
2000 23 juillet Michigan 500 Presented by Toyota Drapeau de la Colombie Juan Pablo Montoya Chip Ganassi Racing Lola Toyota 250 500 (804.672) 2:48:49 177.694
2001 22 juillet Harrah's 500 Presented by Toyota Drapeau du Canada Patrick Carpentier Forsythe Racing Reynard Ford-Cosworth 250 500 (804.672) 2:54:55 171.498
Indy Racing League / IndyCar Series history
2002 28 juillet Michigan Indy 400 Tomas Scheckter Team Cheever Dallara Infiniti 200 400 (643.737) 2:14:03 179.044
2003 27 juillet Firestone Indy 400 Alex Barron Mo Nunn Racing G-Force Toyota 200 400 (643.737) 2:12:39 180.917
2004 1 août Michigan Indy 400 Buddy Rice Rahal Letterman Racing G-Force Honda 200 400 (643.737) 2:11:47 182.123
2005 31 juillet Michigan Indy 400 Bryan Herta Andretti Green Racing Dallara Honda 200 400 (643.737) 2:23:33 167.197
2006 30 juillet Firestone Indy 400 Hélio Castroneves Team Penske Dallara Honda 200 400 (643.737) 2:03:44 193.972
2007 5 août Firestone Indy 400 Tony Kanaan Andretti Green Racing Dallara Honda 200 400 (643.737) 2:49:38 141.481

Notes et références

Liens externes